IMHOFF, Daniel Mathew

IMHOFF, Daniel Mathew

Male 1988 - 2010  (22 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

 1. IMHOFF, Daniel Mathew 
 B: 11 Jun 1988 
 P:  Lake County, CA 
 D: 19 Dec 2010 
 P:  Arizona 
 2. IMHOFF, James Walter 
   
   
   
   
   
   
 4. IMHOFF, Richard Joseph 
 B: 04 Jun 1935 
 P:  Utica, Oneida, New York USA 
 M: 28 Nov 1959 
 P:  Saint Mary's Church Clinton New York 
 D: 25 Sep 2023 
 P:  Clayton, North Carolina 
 8. IMHOFF, Walter J 
 B: 03 Jul 1914 
 P:  New York, New York, USA 
 M: 28 Nov 1934 
 P:  St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York 
 D: 03 Nov 1977 
 P:  Whitesboro, Oneida, New York, United States of America 
 16. IMHOFF, John Frederick 
 B: 05 Dec 1881 
 P:  Utica, Oneida, New York USA 
 M: 21 Jul 1909 
 P:  Whitesboro, Oneida, New York, United States of America 
 D: 29 Jul 1962 
 P:  Whitesboro, Oneida, New York, United States of America 
 32. IMHOFF, Joseph  =>
 B: 26 Sep 1849 
 P:  Oneida, New York, USA 
 M: 12 Jan 1875 
 P:  St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York 
 D: 18 Feb 1937 
 P:  Utica NY (St. Elizabeth's Hospital) 
 33. GENTZ, Louisa  =>
 B: 21 Feb 1852 
 P:  Saxony, Germany 
 D: 18 Dec 1929 
 P:  Utica, Oneida, New York USA 
 17. LANDRY, Rose L 
 B: 1886 
 P:  Sherbrook, Canada 
 D: 31 Jul 1970 
 P:   
 34. LANDRY, Pascal  =>
 A: 1839 
 P:  L`Acadie, Québec (Quebec) 
 M: 1874 
 P:   
 D:  
 P:   
 35. FOURNIER, Marance  =>
 B: Aug 1843 
 P:  Canada French 
 D: 20 Nov 1922 
 P:  Varick Street Utica New York 
 9. CAHOW, Evelyn C 
 B: 18 Apr 1916 
 P:  Marcy, New York 
 D: 03 Nov 1977 
 P:  Marcy, New York 
 18. CAHOW, Raymond Richard 
 B: 07 Dec 1883 
 P:  Mt. Pleasant, Isabella, Michigan, USA 
 M: 22 Jul 1906 
 P:  Thorice Michigan 
 D: 13 May 1961 
 P:  Nyack,Rockland Co.,NY 
 36. CAHOW, William Ransom  =>
 B: 15 Nov 1858 
 P:  Akron,Summit Co.,OH 
 M: 10 Jul 1873 
 P:  Toledo,Lucas Co.,OH 
 D: 10 Nov 1928 
 P:  Newberry, Luce, Michigan, USA 
 37. STOYLE, Henrietta Victoria  =>
 B: 22 Feb 1853 
 P:  Cramma, Hastings, Ontario, Canada 
 D: 13 Apr 1925 
 P:  Oak Ridge Park, Chippewa, Michigan, USA 
 19. LONGHURST, Violet MARY 
 B: Jul 1888 
 P:  Sault St Marie, Michigan 
 D: 05 Oct 1941 
 P:  Rome, Oneida, New York, United States Of America 
 38. LONGHURST, John  =>
 B: 16 Feb 1842 
 P:  Mulmur Township, Simcoe, Ontario, Canada 
 M: 25 Dec 1865 
 P:  Mulmur Township, Simcoe, Ontario, Canada 
 D: 7 Aug 1917 
 P:  Sault St Marie, Michigan 
 39. WHITLEY, Ann  =>
 B: 1848 
 P:  Mulmur Township, Simcoe, Ontario, Canada 
 D:  
 P:  Sault St Marie, Michigan 
 5. PRYOR, Anne Marie 
 B: 10 Mar 1938 
 P:  Utica, Oneida, New York USA 
 D: 14 Sep 2002 
 P:  Verona, Oneida, New York, United States of America 
 10. PRYOR, James Houston 
 B: 05 Apr 1907 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 M: 28 Oct 1936 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 D: 28 Jan 1995 
 P:  Floyd Avenue, Rome New York 
 20. PRYOR, Daniel Henry 
 B: 20 Apr 1872 
 P:  Westmoreland, Oneida, New York, United States 
 M: 31 Oct 1900 
 P:  Saint Mary's Church Clinton New York 
 D: 15 Sep 1953 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 40. PRYOR, James Daniel  =>
 B: 16 Mar 1830 
 P:  Ireland 
 M: 08 Jan 1853 
 P:  Saint Mary's Church Clinton New York 
 D: 16 Oct 1921 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 41. ROBINSON, Margaret 
 B: 1833 
 P:  Ireland 
 D: 1898 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 21. QUINN, Marcella Bridget 
 B: 15 Jan 1875 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 D: 13 Jan 1959 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 42. QUINN, Thomas Foran  =>
 B: Abt 1845 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 1919 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 43. HOUSTON, Alice  =>
 B: 19 Aug 1853 
 P:   
 D: 1933 
 P:   
 11. WELCH, Lorretta Mary 
 B: 19 Jan 1907 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 D: 03 Apr 1964 
 P:  Utica NY (St. Luke's Hospital) 
 22. WELCH, Joseph Lawrence 
 B: 28 Nov 1868 
 P:  Sangerfield, Oneida, New York 
 M: 04 Nov 1903 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 D: 16 May 1936 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 44. WELCH, Luke  =>
 B: 1838 
 P:  Galway, Oranmore, Ireland 
 M:  
 P:   
 D: 04 Feb 1918 
 P:  Oneida County, New York, USA 
 45. DONLON, Mary 
 B: Abt 1831 
 P:  Ireland 
 D: Jun 02 1906 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 23. BOGAN, Mary Agnes 
 B: 10 Jun 1873 
 P:  Sangerfield, Oneida, NY 
 D: 23 Dec 1965 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 46. BOGAN, Lawrence  =>
 B: 1848 
 P:  Wexford, Ireland; Lady's Island Parish; Fern Diocese 
 M: 07 Feb 1873 
 P:  Waterville, Oneida County, New York, USA 
 D: 1929 
 P:   
 47. MCCABE, Bridget  =>
 B: 18 Jul 1852 
 P:  Ireland, Wexford 
 D: 02 Feb 1927 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 3. LEWIS, Michelle 
   
   
   
   
 6.  
   
   
   
   
   
   
 12.  
   
   
   
   
   
   
 24.  
   
   
   
   
   
   
 48.  
   
   
   
   
   
   
 49.  
   
   
   
   
 25.  
   
   
   
   
 50.  
   
   
   
   
   
   
 51.  
   
   
   
   
 13.  
   
   
   
   
 26.  
   
   
   
   
   
   
 52.  
   
   
   
   
   
   
 53.  
   
   
   
   
 27.  
   
   
   
   
 54.  
   
   
   
   
   
   
 55.  
   
   
   
   
 7.  
   
   
   
   
 14.  
   
   
   
   
   
   
 28.  
   
   
   
   
   
   
 56.  
   
   
   
   
   
   
 57.  
   
   
   
   
 29.  
   
   
   
   
 58.  
   
   
   
   
   
   
 59.  
   
   
   
   
 15.  
   
   
   
   
 30.  
   
   
   
   
   
   
 60.  
   
   
   
   
   
   
 61.  
   
   
   
   
 31.  
   
   
   
   
 62.  
   
   
   
   
   
   
 63.