PETRIE, Richard

PETRIE, Richard

Male 1941 - 2013  (72 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media

 1. PETRIE, Richard 
 B: 1 May 1941 
 P:   
 D: 12 May 2013 
 P:  Remsen, New York 
 2. PETRIE, Burton 
 B: 28 Mar 1913 
 P:   
 M: 30 Jan 1935 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 D: 17 Jul 1969 
 P:  St. Elizabeth Hospital, Utica, New York 
 4. PETRIE, Frank E 
   
   
   
   
   
   
 8.  
   
   
   
   
   
   
 16.  
   
   
   
   
   
   
 32.  
   
   
   
   
   
   
 64.  
   
   
   
   
   
   
 128.  
   
   
   
   
   
   
 129.  
   
   
   
   
 65.  
   
   
   
   
 130.  
   
   
   
   
   
   
 131.  
   
   
   
   
 33.  
   
   
   
   
 66.  
   
   
   
   
   
   
 132.  
   
   
   
   
   
   
 133.  
   
   
   
   
 67.  
   
   
   
   
 134.  
   
   
   
   
   
   
 135.  
   
   
   
   
 17.  
   
   
   
   
 34.  
   
   
   
   
   
   
 68.  
   
   
   
   
   
   
 136.  
   
   
   
   
   
   
 137.  
   
   
   
   
 69.  
   
   
   
   
 138.  
   
   
   
   
   
   
 139.  
   
   
   
   
 35.  
   
   
   
   
 70.  
   
   
   
   
   
   
 140.  
   
   
   
   
   
   
 141.  
   
   
   
   
 71.  
   
   
   
   
 142.  
   
   
   
   
   
   
 143.  
   
   
   
   
 9.  
   
   
   
   
 18.  
   
   
   
   
   
   
 36.  
   
   
   
   
   
   
 72.  
   
   
   
   
   
   
 144.  
   
   
   
   
   
   
 145.  
   
   
   
   
 73.  
   
   
   
   
 146.  
   
   
   
   
   
   
 147.  
   
   
   
   
 37.  
   
   
   
   
 74.  
   
   
   
   
   
   
 148.  
   
   
   
   
   
   
 149.  
   
   
   
   
 75.  
   
   
   
   
 150.  
   
   
   
   
   
   
 151.  
   
   
   
   
 19.  
   
   
   
   
 38.  
   
   
   
   
   
   
 76.  
   
   
   
   
   
   
 152.  
   
   
   
   
   
   
 153.  
   
   
   
   
 77.  
   
   
   
   
 154.  
   
   
   
   
   
   
 155.  
   
   
   
   
 39.  
   
   
   
   
 78.  
   
   
   
   
   
   
 156.  
   
   
   
   
   
   
 157.  
   
   
   
   
 79.  
   
   
   
   
 158.  
   
   
   
   
   
   
 159.  
   
   
   
   
 5. NUSSER, Barbara 
   
   
   
   
 10.  
   
   
   
   
   
   
 20.  
   
   
   
   
   
   
 40.  
   
   
   
   
   
   
 80.  
   
   
   
   
   
   
 160.  
   
   
   
   
   
   
 161.  
   
   
   
   
 81.  
   
   
   
   
 162.  
   
   
   
   
   
   
 163.  
   
   
   
   
 41.  
   
   
   
   
 82.  
   
   
   
   
   
   
 164.  
   
   
   
   
   
   
 165.  
   
   
   
   
 83.  
   
   
   
   
 166.  
   
   
   
   
   
   
 167.  
   
   
   
   
 21.  
   
   
   
   
 42.  
   
   
   
   
   
   
 84.  
   
   
   
   
   
   
 168.  
   
   
   
   
   
   
 169.  
   
   
   
   
 85.  
   
   
   
   
 170.  
   
   
   
   
   
   
 171.  
   
   
   
   
 43.  
   
   
   
   
 86.  
   
   
   
   
   
   
 172.  
   
   
   
   
   
   
 173.  
   
   
   
   
 87.  
   
   
   
   
 174.  
   
   
   
   
   
   
 175.  
   
   
   
   
 11.  
   
   
   
   
 22.  
   
   
   
   
   
   
 44.  
   
   
   
   
   
   
 88.  
   
   
   
   
   
   
 176.  
   
   
   
   
   
   
 177.  
   
   
   
   
 89.  
   
   
   
   
 178.  
   
   
   
   
   
   
 179.  
   
   
   
   
 45.  
   
   
   
   
 90.  
   
   
   
   
   
   
 180.  
   
   
   
   
   
   
 181.  
   
   
   
   
 91.  
   
   
   
   
 182.  
   
   
   
   
   
   
 183.  
   
   
   
   
 23.  
   
   
   
   
 46.  
   
   
   
   
   
   
 92.  
   
   
   
   
   
   
 184.  
   
   
   
   
   
   
 185.  
   
   
   
   
 93.  
   
   
   
   
 186.  
   
   
   
   
   
   
 187.  
   
   
   
   
 47.  
   
   
   
   
 94.  
   
   
   
   
   
   
 188.  
   
   
   
   
   
   
 189.  
   
   
   
   
 95.  
   
   
   
   
 190.  
   
   
   
   
   
   
 191.  
   
   
   
   
 3. PRYOR, Alice (Anna) Evelyn 
 B: 14 Dec 1914 
 P:   
 D: 22 Mar 2003 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 6. PRYOR, Daniel Henry 
 B: 20 Apr 1872 
 P:  Westmoreland, Oneida, New York, United States 
 M: 31 Oct 1900 
 P:  Saint Mary's Church Clinton New York 
 D: 15 Sep 1953 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 12. PRYOR, James Daniel 
 B: 16 Mar 1830 
 P:  Ireland 
 M: 08 Jan 1853 
 P:  Saint Mary's Church Clinton New York 
 D: 16 Oct 1921 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 24. PRYOR, John 
   
   
   
   
   
   
 48.  
   
   
   
   
   
   
 96.  
   
   
   
   
   
   
 192.  
   
   
   
   
   
   
 193.  
   
   
   
   
 97.  
   
   
   
   
 194.  
   
   
   
   
   
   
 195.  
   
   
   
   
 49.  
   
   
   
   
 98.  
   
   
   
   
   
   
 196.  
   
   
   
   
   
   
 197.  
   
   
   
   
 99.  
   
   
   
   
 198.  
   
   
   
   
   
   
 199.  
   
   
   
   
 25. KIERNAN, Anne 
   
   
   
   
 50.  
   
   
   
   
   
   
 100.  
   
   
   
   
   
   
 200.  
   
   
   
   
   
   
 201.  
   
   
   
   
 101.  
   
   
   
   
 202.  
   
   
   
   
   
   
 203.  
   
   
   
   
 51.  
   
   
   
   
 102.  
   
   
   
   
   
   
 204.  
   
   
   
   
   
   
 205.  
   
   
   
   
 103.  
   
   
   
   
 206.  
   
   
   
   
   
   
 207.  
   
   
   
   
 13. ROBINSON, Margaret 
 B: 1833 
 P:  Ireland 
 D: 1898 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 26.  
   
   
   
   
   
   
 52.  
   
   
   
   
   
   
 104.  
   
   
   
   
   
   
 208.  
   
   
   
   
   
   
 209.  
   
   
   
   
 105.  
   
   
   
   
 210.  
   
   
   
   
   
   
 211.  
   
   
   
   
 53.  
   
   
   
   
 106.  
   
   
   
   
   
   
 212.  
   
   
   
   
   
   
 213.  
   
   
   
   
 107.  
   
   
   
   
 214.  
   
   
   
   
   
   
 215.  
   
   
   
   
 27.  
   
   
   
   
 54.  
   
   
   
   
   
   
 108.  
   
   
   
   
   
   
 216.  
   
   
   
   
   
   
 217.  
   
   
   
   
 109.  
   
   
   
   
 218.  
   
   
   
   
   
   
 219.  
   
   
   
   
 55.  
   
   
   
   
 110.  
   
   
   
   
   
   
 220.  
   
   
   
   
   
   
 221.  
   
   
   
   
 111.  
   
   
   
   
 222.  
   
   
   
   
   
   
 223.  
   
   
   
   
 7. QUINN, Marcella Bridget 
 B: 15 Jan 1875 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 D: 13 Jan 1959 
 P:  Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York 
 14. QUINN, Thomas Foran 
 B: Abt 1845 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 1919 
 P:  Clinton, Oneida County, New York 
 28. QUINN, Bartholomew 
 B:  
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 1850 
 P:  Geashill, Offaly (Kings) County, Ireland 
 56.  
   
   
   
   
   
   
 112.  
   
   
   
   
   
   
 224.  
   
   
   
   
   
   
 225.  
   
   
   
   
 113.  
   
   
   
   
 226.  
   
   
   
   
   
   
 227.  
   
   
   
   
 57.  
   
   
   
   
 114.  
   
   
   
   
   
   
 228.  
   
   
   
   
   
   
 229.  
   
   
   
   
 115.  
   
   
   
   
 230.  
   
   
   
   
   
   
 231.  
   
   
   
   
 29. FORAN, Bridget 
   
   
   
   
 58.  
   
   
   
   
   
   
 116.  
   
   
   
   
   
   
 232.  
   
   
   
   
   
   
 233.  
   
   
   
   
 117.  
   
   
   
   
 234.  
   
   
   
   
   
   
 235.  
   
   
   
   
 59.  
   
   
   
   
 118.  
   
   
   
   
   
   
 236.  
   
   
   
   
   
   
 237.  
   
   
   
   
 119.  
   
   
   
   
 238.  
   
   
   
   
   
   
 239.  
   
   
   
   
 15. HOUSTON, Alice 
 B: 19 Aug 1853 
 P:   
 D: 1933 
 P:   
 30. HOUSTON, William 
 B: 1827 
 P:   
 M:  
 P:   
 D: 2 Sep 1909 
 P:  Taberg, New York 
 60. HOUSTON, Patrick 
 B: 17 Mar 1784 
 P:  Ireland 
 M: Oct 1826 
 P:   
 D: 17 May 1876 
 P:  Fairfield, Franklin County, Vermont, USA 
 120. HOUSTON, George 
 B: 1769 
 P:  Kilkeel, County Down, Ireland 
 M:  
 P:   
 D: 15 Aug 1836 
 P:   
 240. HOUSTON, William  =>
 B: 1715 
 P:  Ireland 
 M:  
 P:   
 D: 29 Aug 1784 
 P:   
 241. LEATHLY, Elizabeth 
   
   
   
   
 121. FERGUSON, Mary Anne 
 B: 1772 
 P:  Saint Peter, Drogheda, Louth, Ireland 
 D: 21 Oct 1834 
 P:  Drogheda, County Louth, Ireland 
 242. FERGUSON, Joseph 
   
   
   
   
   
   
 243. FAGAN, Judith 
   
   
   
   
 61. SLOANE, Sarah 
 B:  
 P:   
 D: Nov 1 1846 
 P:  Vermont, USA 
 122. SLOANE, William 
   
   
   
   
   
   
 244.  
   
   
   
   
   
   
 245.  
   
   
   
   
 123. UNKNOWN, Catherine 
   
   
   
   
 246.  
   
   
   
   
   
   
 247.  
   
   
   
   
 31. LAPPIN, Alice 
 B: 30 Sep 1828 
 P:  Armagh, Armagh, Northern Ireland 
 D: 12 Dec 1886 
 P:  Taberg, Oneida County, New York, United States of America 
 62. LAPPIN, Patrick 
 B: 1784 
 P:  County Armag, Ireland 
 M:  
 P:   
 D: 31 Jul 1876 
 P:  Annsville, NY 
 124. LAPPIN, Bernard 
 B: 1770 
 P:  Armagh, Northern Ireland 
 M:  
 P:   
 D: 12 Nov 1847 
 P:  St Sylvestre, Quebec, Canada 
 248.  
   
   
   
   
   
   
 249.  
   
   
   
   
 125. ROURKE, Bridget 
 B: 1772 
 P:  Ireland 
 D: 14 Nov 1847 
 P:  Ireland 
 250. ROURKE, Laurence 
   
   
   
   
   
   
 251.  
   
   
   
   
 63. MCGINN, Cecelia 
 B: 1802 
 P:  County Armag, Ireland 
 D: 1881 
 P:  Annsville, NY 
 126.  
   
   
   
   
   
   
 252.  
   
   
   
   
   
   
 253.  
   
   
   
   
 127.  
   
   
   
   
 254.  
   
   
   
   
   
   
 255.